PART I / PARTIE I Volume 37, No. 12 / Volume 37, n o 12

Similar documents
PART I / PARTIE I Volume XXX, No. 11 / Volume XXX, n o 11

PART I / PARTIE I Volume 36, No. 1 / Volume 36, n o 1

PART I / PARTIE I Volume 37, No. 9 / Volume 37, n o 9

HOLA SAFETY RING PLAN

Nunavut Gazette Gazette du Nunavut

Dangerous Goods Handling and Règlement sur la manutention et le transport

The Nation Municipality Municipalité de La Nation. Budget 2007 Presented on May 7th Présenté le 7 mai

I lf:,jo ~ S-o 3S9~75"97. ARRETE NO. Z lOZ. BY-LAW NO. Z lOZ. A by-law amending Zoning By-Law Z of the Town of Shediac

Benin Tourist visa Application for citizens of Bangladesh living in Alberta

1. CANADA DAY 2012 PARKING LOT PARTIES IN THE BYWARD MARKET FÊTE DU CANADA 2012 CÉLÉBRATIONS TENUES DANS LE PARC DE STATIONNEMENT DU MARCHÉ BY

1. Configurez votre Stick Up Cam Wired dans l application Ring.

Manuel des statuts et règlements du Comité de liaison UMCE.

WELCOME TO ALL OUR VOLVO S AMATEURS FRIENDS

THE YUKON GAZETTE LA GAZETTE DU YUKON

A CES CAUSES, Sa Majeste, sur I'avis et du consentement de I' Assemblee legislative du Nouveau-Brunswick, decrete:

Présentation officielle du budget de 2016 le 25 janvier Official Presentation of the 2016 Budget January 25 th, 2016

ORD ORDRE DU JOUR AGENDA. Approval of minutes of the regular sitting of February and the special sitting of February

Tuesday June 5 th, 2018

COURT OF APPEAL COUR D APPEL NOUVEAU-BRUNSWICK NEW BRUNSWICK. List of Cases for the November 2016 sitting

Nouvelles vedettes et vedettes révisées du CSH sur le Web (no de contrôle de la BNC sont inclus) mai 2004

SEDI Contact Information

Capital Estimates. Budget de capital

Nunavut Gazette Gazette du Nunavut

MANITOBA GOVERNMENT PUBLICATIONS MONTHLY CHECKLIST PUBLICATIONS DU GOUVERNEMENT DU MANITOBA: LISTE MENSUELLE

Dehcho Settlement Region Contacts

Revised: February 2017 Page 1

ESPACE DES ONG / NGO SPACE 39 e session de la Conférence générale / 39 th session of the General Conference

GUIDE D INSTALLATION PVC CELLULAIRE

BANQUE DE DONNEES MINIERES DU GROUPE DES ETATS ACP

Capital Estimates. Budget de capital

Federal Central Authority Address Telephone/ Fax and website Languages spoken by staff. Tel: +1 (343)

Manitoba Government Job Opportunities Advertisement No Department(s): Salary(s): Closing Date: Apply To:

INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE

The Kitigan Zibi Reserve is located 130 kilometres north the new amalgamated city of Gatineau.

Développement d Application & interface Web-BDD

Ministerial Travel Report April to June 2015

LITERACY IN NOVA SCOTIA Implications of Findings from IALSS 2003

Roll Up 28. Ref A. DE Anleitung FR Notice ES Manual PT Instruções PL Instrukcja RU Руководство CS Návod

CONVENTION GREETINGS, NOVEMBER 20 24, Patty Coates Secretary-Treasurer. SHERATON CENTRE TORONTO HOTEL Toronto, Ontario

CERTIFICATE OF CLASSIFICATION

How french institutions promote and frame the energy action of local authorities?

NORTHWEST TERRITORIES PARKS FACT SHEET

SCADE for AIRBUS critical avionics systems

Musique Cordiale, Association Fr

ORD ORDRE DU JOUR AGENDA. Approval of minutes of the regular sitting of July and special sitting of July ADMINISTRATION / LEGISLATION

1 The Cadastral Mapping Fee Order (AR 94/2000) is amended by this Regulation.

Plan of Subdivision Proposal, Official Plan Amendment, and Zoning By-law Amendment Summary

CONVOCATION The Westin Zagreb Krsnjavoga 1 Zagreb, CROATIA : (385) (1) : (385) (1)

TABLE OF PROVISIONS BROUGHT INTO FORCE

PROPRIÉTAIRES - PARTENAIRES OWNERS PARTNERS. Réunion annuelle - General Membership Meeting 2015 Official Presentation

Organisation de Coopération et de Développement Économiques Organisation for Economic Co-operation and Development

Annual Report

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

An Unclaimed Intangible Property Program for Ontario

DEMANDE DE BOURSE FONDS DES ARTS. Avril janvier, 16 h 30 PROCHAINE ÉMISSION : REMISE DU FORMULAIRE AVANT LE :

I We reserve the right to modify or attar Instructions. No modification or

CORPORATION OF THE CITY OF CLARENCE-ROCKLAND COMMITTEE OF ADJUSTMENT

G azette. Gazette. Manitoba. Manitoba THE. Table of Contents. Vol. 146 No. 9 March 4, 2017 Winnipeg le 4 mars 2017 Vol. 146 n o 9

Rapport d'activités des CN 2007 Activity Report Form 2007

The Saskatchewan Gazette PUBLISHED WEEKLY BY AUTHORITY OF THE QUEEN S PRINTER/PUBLIÉE CHAQUE SEMAINE SOUS L AUTORITÉ DE L IMPRIMEUR DE LA REINE

Decision Enacting the Law on Salaries and Other Compensations in Judicial and Prosecutorial Institutions at the Level of Bosnia and Herzegovina

Présentation officielle du budget de 2015 le 9 février Official Presentation of the 2015 Budget February 9 th, 2015

Procurement Plan. I. General

THE NEWFOUNDLAND AND LABRADOR GAZETTE

Burkina Faso Tourist visa Application

Thermographie, pourquoi l utiliser?

The European Association of Middle East Librarians Association européenne des bibliothécaires du Moyen-Orient

0000 NAME: P.C.: L7C1J6 CONTACT: If necessary, please update above information - Si nécessaire, veuillez mettre à jour les renseignements ci-dessus

IMPORTANT SAFETY RECALL

To advance the cause and pursue the objectives of the American Inns of Court as hereinafter set forth.

Plan of Subdivision & Zoning By-Law Amendment Proposal Summary

COURT OF APPEAL COUR D APPEL NOUVEAU-BRUNSWICK NEW BRUNSWICK. List of Cases for the April 2018 sitting

CAISSE NATIONALE DES CAISSES D EPARGNE ET DE PREVOYANCE


MEMBER REGULATION. notice

1. Acting Deputy City Manager s report, Planning and Infrastructure, dated 23 June 2015 (ACS2015-PAI-INF-0003).

The Amusement Ride Safety Act

Unclaimed Financial Assets

PUBLIC ACCOUNTABILITY PRINCIPLES FOR CANADIAN AIRPORT AUTHORITIES

Bill S-5: An Act to amend the Canada National Parks Act (Nááts ihch oh National Park Reserve of Canada)

The Alberta Gazette. Part I. Vol. 103 Edmonton, Monday, January, 2007 No. 1 RESIGNATIONS & RETIREMENTS. (Justice of the Peace Act)

CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF BONNECHERE VALLEY BY-LAW # Being a By-Law to provide for Cash in Lieu of Required Parking Spaces

1. Information générale 1. General information

BERMUDA 1994 : 2 MERCHANT SHIPPING (DEMISE CHARTER) ACT 1994

Name: Crossword: Canada ACROSS. 5. The bilingual province. 6. The only French province. 10. It's capital city is Winnipeg. 12. Capital of Canada.

"THE STATE OF QUALITY MEASURES IN CANADA KATHLEEN FLANAGAN

Call to Book:

IMPORTANT SAFETY RECALL

Transport Canada - Civil Aviation Service Standards Performance Report Regulatory Fee: Yes (Adjusted for Client Response Time)

INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE

On July 20, 2017, the Premier's Office received your request for access to the following records/information:

TECHNICAL SPECIFICATION SPÉCIFICATION TECHNIQUE

STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH Section Animal Health and Welfare

COUNCIL MINUTES 1. WELCOME 2. REVIEW AGENDA. May 22, 2013 Hotel Gander

STATEMENT OF TREATIES AND INTERNATIONAL AGREEMENTS Registered or filed and recorded with the Secretariat during the month of April 2014

Rapport d'activités des CN 2014 NC Activity Report Form Information générale 1. General information

1. Information générale 1. General information

NOTICE OF PROPOSED AMENDMENT (NPA) AVIS DE PROPOSITION DE MODIFICATION (APM)

CHAPTER FISHERY LIMITS ORDINANCE and Subsidiary Legislation

The Operating Authority Regulations, 2011

Transcription:

PART I / PARTIE I Volume 37, No. 12 / Volume 37, n o 12 Yellowknife, Northwest Territories / Territoires du Nord-Ouest 2016-12-16 ISSN 2291-0409 (Online / en ligne) NOTICE AVIS The full text of an appointment may be viewed at the Office of the Registrar of Regulations, 5 th floor Courthouse, Yellowknife, NT X1A 2L9. Le texte intégral d une nomination peut être examiné au bureau du registraire des règlements, Palais de Justice, 5 e étage, Yellowknife (NT) X1A 2L9. APPOINTMENTS / NOMINATIONS Appointee/Titulaire Address/Adresse Registration No./ N o d enregistrement Term/ Durée du mandat Effective Date/ Date d entrée en fonctions As Adoption Workers for the Northwest Territories under the Adoption Act: Préposées à l adoption des Territoires du Nord-Ouest en vertu de la Loi sur l adoption : ARMSTRONG, Chelsey Yellowknife A-475-2016 2016-11-17 BAILEY, Denise Behchokö A-476-2016 2016-11-17 MADIRATTA, Dolly Norman Wells A-477-2016 2016-11-17 PELLEY, Nicole Yellowknife A-478-2016 2016-11-17 PIERROT, Delphine Fort Simpson A-479-2016 2016-11-17 SELAMIO, Lena Tuktoyaktuk A-480-2016 2016-11-17 SPENCER, Kassandra Hay River A-481-2016 2016-11-17 As Director of Apprenticeship, Trade and Occupation Certification under the Apprenticeship, Trade and Occupation Certification Act: Directeur de l apprentissage et de la qualification professionnelle des métiers et professions en vertu de la Loi sur les l apprentissage et de la qualification professionnelle des métiers et professions : SATURNINO, Michael Yellowknife A-468-2016 2016-11-14 200

Appointee/Titulaire Address/Adresse Registration No./ N o d enregistrement Term/ Durée du mandat Effective Date/ Date d entrée en fonctions As a member of the Board of Governors of Aurora College under the Aurora College Act: Membre du Conseil des gouverneurs du Collège Aurora en vertu de la Loi sur le Collège Aurora : KOE, William Fort McPherson A-483-2016 3 years/3 ans As Child Protection Workers for the Northwest Territories under the Child and Family Services Act: Préposées à la protection de l enfance des Territoires du Nord-Ouest en vertu de la Loi sur les services à l enfance et à la famille : CHERWATY, Kyla Yellowknife A-472-2016 2016-11-14 PIERROT, Delphine Fort Simpson A-473-2016 2016-11-09 REGNIER, Melissa Yellowknife A-474-2016 2016-11-30 As members of the N.W.T. Teacher Qualification Service under the Education Act: Membres du Services d examen des compétences des enseignants des T.N.-O. en vertu de la Loi sur l éducation : GIESBRECHT, Andrea Yellowknife A-484-2016 from/de OLIVER, Fraser Yellowknife A-485-2016 from/de PARKER, Claudia Yellowknife A-486-2016 from/de SIMMONS, Katey Yellowknife A-487-2016 from/de As a member of the Hay River Housing Authority under the Northwest Territories Housing Corporation Act: Membre de l Office d habitation de Hay River en vertu de la Loi sur la Société d habitation des Territoires du Nord- Ouest : CAUDRON, Cynthia Anne Hay River A-469-2016 from/de 2016-12-06 to/à 2019-12-05 2016-12-06 As Territorial Printer under the Public Printing Act: Imprimeur territorial en vertu de la Loi sur les publications officielles : REDDY, Mike Yellowknife A-482-2016 2016-11-14 As safety officers under the Safety Act: Agents de sécurité en vertu de la Loi sur la sécurité : ABBOTT, Mark Iqaluit, NU A-493-2016 2016-12-06 BREUTIGAM, Ron Yellowknife A-494-2016 2016-12-06 As members of the Student Financial Assistance Appeal Board under the Student Financial Assistance Act: Membres de la Commision d appel de l aide financière aux étudiants en vertu de la Loi sur l aide financière aux étudiants : GAUTHIER, Brenda Yellowknife A-488-2016 from/de HERNANDEZ, Moses Inuvik A-489-2016 from/de LEESON, Nick Yellowknife A-490-2016 from/de MOORMAN, Darren Tulita A-491-2016 from/de WOOD, Clarence Inuvik A-492-2016 from/de 201

Appointee/Titulaire Address/Adresse Registration No./ N o d enregistrement As the Workers Advisor under the Workers Compensation Act: Conseiller des travailleurs en vertu de la Loi sur l indemnisation des travailleurs : Term/ Durée du mandat Effective Date/ Date d entrée en fonctions SCOTT, Patrick Yellowknife A-471-2016 2017-01-01 As a member of the Ulukhaktok Youth Justice Committee under the Youth Justice Act: Membre du comité de justice pour la jeunesse de Ulukhaktok en vertu de la Loi sur le système de justice pour les adolescents : OKHEENA-ALONAK, Marie Adele Ulukhaktok A-470-2016 3 years/3 ans 2016-12-06 202

REVOCATIONS / RÉVOCATIONS Name/Nom Revocation No./ N o de révocation Effective Date/ Date d entrée en fonctions Original Appointment/ Première nomination Apprenticeship, Trade and Occupation Certification Act: Supervisor of Apprenticeship, Trade and Occupations Certification Loi sur l apprentissage et de la qualification professionnelle des métiers et professions : surveillante de l apprentissage et de la qualification professionnelle des métiers et professions MORTON, Laurie AR-261-2016 2016-11-14 A-201-2011 Child and Family Services Act: Child Protection Worker for the Northwest Territories Loi sur les services à l enfance et à la famille : préposée à la protection de l enfance des Territoires du Nord-Ouest ANSTEY, Brenda AR-265-2016 2016-10-15 A-062-2014 Liquor Act: inspector Loi sur les boissons alcoolisées : inspectrice DAIGNEAULT, Kirsten Amber AR-262-2016 2016-11-01 A-332-2012 Marriage Act: issuer of marriage licences Loi sur le mariage : délivreur de licences de mariage BISHOP, Reverend John Albert AR-272-2016 1982-11-30 NS-0025-79 Marriage Act: marriage commissioners Loi sur le mariage : commissaires aux mariages DUBÉ, Anita AR-266-2016 2016-11-24 A-019-2002 LOOMIS, Monica AR-267-2016 2016-11-24 A-252-96 STEINER, Ray AR-268-2016 2016-11-24 A-561-2015 VILLENEUVE, Terry AR-269-2016 2016-11-24 A-022-2002 WENINGER, Josephine Mary Eleanor AR-270-2016 2016-11-24 A-024-2007 Prisons and Reformatories Act (Canada): officer responsible for authorizing temporary absences Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) : responsable de l octroi des permissions de sortir GROENHEYDE, Quinn AR-263-2016 2016-11-18 A-605-97 Public Printing Act: Territorial Printer Loi sur les publications officielles : imprimeuse territoriale MCLAUGHLIN, Kelly Lynn AR-271-2016 2016-11-14 A-319-2012 Workers Compensation Act: Workers Advisor Loi sur l indemnisation des travailleurs : conseiller des travailleurs TKACHUK, Garry AR-264-2016 2016-12-31 A-192-2014 203

GOVERNMENT NOTICES (REGISTRIES) / AVIS DU GOUVERNEMENT (BUREAUX D ENREGISTREMENT) BUSINESS CORPORATIONS ACT LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS NOTICES OF INCORPORATION OF TERRITORIAL CORPORATIONS (section 8): AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS TERRITORIALES (article 8) : Corporation/ Société par actions Corporation No./ N o de la société par actions Registered Office/ Bureau enregistré Date of Incorporation/ Date de la constitution DENENDEH FOOD SERVICES LTD. 507099 5107 53 rd Street P.O. Box 2910 Yellowknife NT X1A 2R2 AWARD COMMUNICATIONS INC. 507100 601-4920 52 nd Street Yellowknife NT X1A 3T1 BAOYU AURORA TOUR LTD. 507101 5113 54 th Street Yellowknife NT X1A 1W6 NWT DIAMOND VALUATORS INC. 507102 5107 53 rd Street P.O. Box 2910 Yellowknife NT X1A 2R2 507103 N.W.T. LTD. 507103 5016 47 th Street P.O. Box 383 Yellowknife NT X1A 2N3 2016-11-18 2016-11-21 2016-11-30 2016-12-07 2016-12-07 NOTICES OF CHANGE OF NAME OF TERRITORIAL CORPORATIONS [subsections 13(4) and 179(2)]: AVIS DE CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS TERRITORIALES [paragraphes 13(4) et 179(2)] : Former Name / Ancienne dénomination sociale Corporation No. / N o de la société par actions New Name / Nouvelle dénomination sociale Date of Change / Date du changement RED RIVER INCORPORATED BAND LTD. 505972 RED RIVER DEVELOPMENT CORPORATION 2016-12-02 506492 N.W.T. LTD. 506492 ABORIGINAL ENVIRONMENTAL REMEDIATION CORPORATION 2016-11-25 204

NOTICES OF AMENDMENT OF ARTICLES OF TERRITORIAL CORPORATIONS [subsection 29(6) or section 180]: AVIS DE MODIFICATION DES STATUTS DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS TERRITORIALES [paragraphe 29(6) ou article 180] : Corporation/ Société par actions Corporation No./ N o de la société par actions Date of Amendment/ Date de la modification RIX TRUCKING (FORT RAE 1976) LTD. 500670 2016-11-30 943443 N.W.T. LTD. 503443 2016-11-30 RED RIVER DEVELOPMENT CORPORATION 505972 2016-12-02 ABORIGINAL ENVIRONMENTAL REMEDIATION CORPORATION 506492 2016-11-25 C.A.B. CONSTRUCTION LTD. 506976 2016-12-02 QUALITY HOUSES CONSTRUCTION LTD. 507098 2016-11-22 NOTICES OF INTENT TO DISSOLVE TERRITORIAL CORPORATIONS [subsections 214(2), 214(3), 214(4) or 214(5)]: AVIS D INTENTION DE DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS TERRITORIALES [paragraphes 214(2), 214(3), 214(4) ou 214(5)] : Corporation / Société par actions Corporation No. / N o de la société par actions Date of Notice / Date de l avis 506711 N.W.T. LIMITED 506711 2016-11-22 NOTICES OF REGISTRATION OF EXTRA-TERRITORIAL CORPORATIONS [subsection 285(1)]: AVIS D ENREGISTREMENT DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS EXTRATERRITORIALES [paragraphe 285(1)] : Corporation / Société par actions Corporation No. / N o de la société par actions Registered Office / Bureau enregistré Jurisdiction / Autorité législative Date of Registration / Date de l enregistrement ROOTS AND RUMINANTS INC. 611967 41 McDougal Road Box 552 Fort Smith NT X0E 0P0 Canada 2016-11-17 1090247 B.C. LTD. 611969 601-4920 52 nd Street Yellowknife NT X1A 3T1 535862 YUKON INC. 611970 7-5120 49 th Street Yellowknife NT X1A 1P8 LBC CAPITAL INC. 611971 601-4920 52 nd Street Yellowknife NT X1A 3T1 British Columbia 2016-11-21 Yukon 2016-11-21 Canada 2016-11-23 205

5530 NUNAVUT INC. 611973 5107 53 rd Street P.O. Box 2910 Yellowknife NT X1A 2R2 Nunavut 2016-11-24 AFFILIATED ENGINEERS NW, INC. HEALTHTEK ENTERPRISES INC. MONERIS SERVICES CORPORATION 611974 601-4920 52 nd Street Yellowknife NT X1A 3T1 611975 301-5109 48 th Street Yellowknife NT X1A 1N5 611976 601-4920 52 nd Street Yellowknife NT X1A 3T1 Washington 2016-11-25 British Columbia 2016-11-28 Ontario 2016-11-28 CI INVESTMENTS INC. 611977 YK Centre East 200-4915 48 th Street P.O. Box 818 Yellowknife NT X1A 2N6 9965661 CANADA LTD. 611978 YK Centre East 200-4915 48 th Street P.O. Box 818 Yellowknife NT X1A 2N6 Ontario 2016-11-29 Canada MACLAB PROPERTIES GROUP LTD. LAWSON PRODUCTS INC. (ONTARIO) 611982 5107 53 rd Street P.O. Box 2910 Yellowknife NT X1A 2R2 611983 601-4920 52 nd Street Yellowknife NT X1A 3T1 Alberta 2016-12-05 Ontario 2016-12-08 NOTICES OF CHANGE OF NAME OF EXTRA-TERRITORIAL CORPORATIONS [subsection 289(4)]: AVIS DE CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS EXTRATERRITORIALES [paragraphe 289(4)] : Name of Corporation / Dénomination sociale de la société par actions Corporation No. / N o de la société par actions New Name of Corporation / Nouvelle dénomination sociale de la société par actions Effective Date / Date de prise d effet GE CAPITAL CANADA FINANCE INC. / FINANCEMENT GE CAPITAL CANADA INC. 609393 GE CAPITAL CANADA FINANCE COMPANY / FINANCEMENT GE CAPITAL CANADA COMPANY 2016-10-01 FAM GPCO INC. 610788 SLATE OFFICE GP INC. 2016-02-29 9335-1252 QUÉBEC INC. 611919 DESJARDINS RÉSEAU INDÉPENDANT ASSURANCES INC. DESJARDINS INDEPENDENT NETWORK INSURANCE INC. 2016-10-26 206

TOSHIBA CLIENT SOLUTIONS CANADA LTD. TOSHIBA CLIENTS SOLUTIONS CANADA LTÉE WESTERN PACIFIC ENTERPRISES LTD. 611920 TOSHIBA CLIENT SOLUTIONS CANADA LTD. TOSHIBA SOLUTIONS CLIENTS CANADA LTÉE 611968 FETTBACK & MOORE HOLDINGS LTD. 2016-09-29 2016-11-01 NOTICES OF AMALGAMATION OF EXTRA-TERRITORIAL CORPORATIONS [subsection 290(2)]: AVIS DE FUSION DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS EXTRATERRITORIALES [paragraphe 290(2)] : Corporation / Société par actions Corporation No. / N o de la société par actions Amalgamating Corporations / Sociétés par actions fusionnées Date of Amalgamation / Date de la fusion BREAKTHRU BEVERAGE CANADA INC. VINS ET SPIRITUEUX BREAKTHRU CANADA INC. SCOTIA REALTY LIMITED/SERVICES IMMOBILIERS SCOTIA LIMITÉE AGILENT TECHNOLOGIES CANADA INC. 611964 611911: BREAKTHRU BEVERAGE CANADA INC.; VINS ET SPIRITUEUX BREAKTHRU CANADA INC.; B AND W WINES LIMITED; CAMJO2 HOLDINGS LIMITED; RIDLEY 64 HOLDINGS LIMITED; SJS1 HOLDINGS LIMITED 611965 609995: SCOTIA REALTY LIMITED / SERVICES IMMOBILIERS SCOTIA LIMITÉE; 789183 ONTARIO LIMITED; 957160 ONTARIO LIMITED; 1957864 ONTARIO INC.; 775767 ONTARIO LIMITED; 1149203 ONTARIO INC. 611966 610193: AGILENT TECHNOLOGIES CANADA INC.; DAKO CANADA ULC 2016-10-31 2016-11-01 2016-11-01 FETTBACK & MOORE HOLDINGS LTD. 611968 611806: WESTPAC ELECTRIC LTD.; WESTERN PACIFIC ENTERPRISES LTD. 2016-10-19 HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE L'AVC DU CANADA RAYMOND JAMES LTD. RAYMOND JAMES LTÉE 611972 607318: HEART AND STROKE FOUNDATION OF ALBERTA, NWT & NUNAVUT; 611126: HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE L'AVC DU CANADA 611979 607823: MACDOUGALL, MACDOUGALL & MACTIER INC.; 611168: RAYMOND JAMES LTD. / RAYMOND JAMES LTÉE 2016-09-01 2016-10-01 207

HEWLETT-PACKARD (CANADA) CO. HEWLETT-PACKARD (CANADA) CIE ROYNAT CAPITAL INC. CAPITAL ROYNAT INC. CIT FINANCIAL LTD. / SERVICES FINANCIERS CIT LTEE 611980 611164: HEWLETT-PACKARD (CANADA) CO. HEWLETT- PACKARD (CANADA) CIE; HEWLETT-PACKARD CANADA INVESTMENTS II CO. 611981 606931: ROYNAT CAPITAL INC. / CAPITAL ROYNAT INC.; ROYNAT MANAGEMENT INC.; ROYDOLCO INC. 611984 610712: CIT CANADA EQUIPMENT RECEIVABLES LTD.; 609446: CIT FINANCIAL LTD. / SERVICES FINANCIERS CIT LTEE 2016-11-01 2016-11-01 2016-09-30 NOTICES OF CANCELLATION OF REGISTRATION OF EXTRA-TERRITORIAL CORPORATIONS [subsection 294(6)]: AVIS D ANNULATION DE L ENREGISTREMENT DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS EXTRATERRITORIALES [paragraphe 294(6)]: Corporation / Société par actions Corporation No. / N o de la société par actions Date of Cancellation / Date de l annulation SILPADA DESIGNS CANADA COMPANY 609391 2016-12-09 VITOL INC. 610679 2016-11-22 1693987 ALBERTA LTD. 611226 TRANSITION METALS CORP. 611677 2016-11-22 NOTICES OF REINSTATEMENT OF REGISTRATION OF EXTRA-TERRITORIAL CORPORATIONS [subsection 295(2)]: AVIS DE REMISE EN VIGUEUR DE L ENREGISTREMENT DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS EXTRATERRITORIALES [paragraphe 295(2)]: Corporation / Société par actions Corporation No. / N o de la société par actions Date of Reinstatement / Date de la remise en vigueur HEART AND STROKE FOUNDATION OF ALBERTA, NWT & NUNAVUT 607318 2016-11-23 208

SOCIETIES ACT LOI SUR LES SOCIÉTÉS NOTICES OF INCORPORATION OF SOCIETIES [subsection 4(4)]: AVIS DE CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE [paragraphe 4(4)] : Name / Dénomination sociale Incorporation No. / N o de constitution Location of Operations / Lieu d'exercice des activités Incorporation Date / Date de constitution TUKTOYAKTUK COMMUNITY GARDEN 702004 Tuktoyaktuk 2016-11-25 NWT 55+ GAMES ASSOCIATION 702005 Yellowknife 2016-11-30 FORT SMITH SNOWBOARDING SOCIETY 702006 Fort Smith 2016-12-09 NOTICES OF CHANGE OF NAME OF SOCIETIES [subsection 23(4)]: AVIS DE MODIFICATION DE DÉNOMINATION D UNE SOCIÉTÉ [paragraphe 23(4)] : Former Name/ Ancienne dénomination sociale Incorporation No./ No de constitution New Name/ Nouvelle dénomination sociale Date of Resolution/ Date de la résolution Date of Change/ Date de la modification GREAT SLAVE SNOWMOBILE ASSOCIATION - TRAIL RIDERS 701777 GREAT SLAVE SNOWMOBILE ASSOCIATION 2016-11-21 2016-11-21 209

GOVERNMENT NOTICES (MISCELLANEOUS) / AVIS DU GOUVERNEMENT (DIVERS) CHANGE OF NAME ACT / LOI SUR LE CHANGEMENT DE NOM The following changes of names have been registered under the Change of Name Act and are hereby published in accordance with section 14 of that Act: / Les changements de nom qui suivent ont été enregistrés en application de la Loi sur le changement de nom et sont, par les présentes, publiés en conformité avec l article 14 de cette loi. FORMER SURNAME / GIVEN NAMES ANCIEN NOM DE FAMILLE / ANCIENS PRÉNOMS DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy) / DATE DE NAISSANCE (jour/mois/année) COMMUNITY OF RESIDENCE / COLLECTIVITÉ OÙ LA PERSONNE RÉSIDE REVISED NAME (SURNAME/GIVEN) / NOUVEAU NOM (NOM DE FAMILLE/PRÉNOMS) EFFECTIVE DATE (dd/mm/yyyy) / DATE DE PRISE D EFFET (jour/mois/année) Kossatz/Carson Joseph 23/12/2006 Yellowknife Darlington/Carson Joseph 09/11/2016 Billan/Jaspal Singh 09/09/1947 Yellowknife Billan/Paul Singh 17/11/2016 Snow/Sommer Elizabeth Mary 31/05/2000 Yellowknife Snow/Spencer Ezra Marshall 24/11/2016 Beaulieu/Marie Germaine Therese 19/05/1949 Yellowknife Beaulieu/Germaine Marie Therese 28/11/2016 210

MISCELLANEOUS NOTICES/AVIS DIVERS NOTICE LEGAL PROFESSION ACT IN THE MATTER of the Legal Profession Act, R.S.N.W.T. 1988, c. L-2; AND IN THE MATTER of the nominations and elections conducted under the Rules of the Law Society of the Northwest Territories which were established by virtue of paragraphs 8(1)(l) and (n) of the Legal Profession Act, R.S.N.W.T. 1988, c. L-2, providing for the nomination and election of members of the Executive of the Law Society of the Northwest Territories; THAT NOTICE THAT on Friday, December 2nd, 2016 at the office of the Law Society, the votes were tabulated by the Executive Director in the presence of and with the assistance of Savannah Noel from the Society's auditor, Crowe MacKay LLP. AND THAT 112 ballots were received of which 1 was rejected as invalid. The following members were elected to the Executive. Tracy Bock for a term of three years Alex Godfrey for a term of two years Ronald Ian MacKay Rennie for a term of three years Candace Seddon for a term of three years The first meeting of the Executive was held following the Annual General Meeting on December 3, 2016. The new Executive determined the Executive roles as follows: President Glen Rutland Vice President Alex Godfrey Secretary Ronald Ian MacKay Rennie Treasurer Alex Godfrey Member at Large Candace Seddon Layperson Heather Chang AVIS LOI SUR LA PROFESSION D AVOCAT DANS L AFFAIRE de la Loi sur la profession d avocat, L.R.T.N.-O, 1998, ch. L-2; ET DANS L AFFAIRE concernant les nominations et les élections tenues en vertu des Règles du Barreau des Territoires du Nord-Ouest prises en vertu des alinéas 8(1)l) et n) de la Loi sur la profession d avocat, L.R.T.N.-O. 1988, ch. L-2, portant nomination et élection des membres du bureau du Barreau des Territoires du Nord-Ouest. AVIS est par les présentes donné que le 2 décembre 2016, les bulletins de vote ont été dépouillés dans les bureaux du Barreau par la directrice exécutive en présence et avec l aide de Savannah Noel, vérificatrice du Barreau, de Crowe MacKay LLP. ET QUE 112 bulletins ont été reçus donc 1 a été rejeté pour avoir été déclaré invalide. Les membres suivants ont été élus au bureau. Tracy Bock pour un terme de trois ans Alex Godfrey pour un terme de deux ans Ronald Ian MacKay Rennie pour un terme de trois ans Candace Seddon pour un terme de trois ans La première réunion du bureau a été tenue suite à l assemblée générale annuelle du 3 décembre 2016. Le nouveau bureau a assigné les postes du bureau comme suit : Président Glen Rutland Vice President Alex Godfrey Secrétaire Ronald Ian MacKay Rennie Trésorier Alex Godfrey Membre en général Candace Seddon Personne profane Heather Chang DATED at the City of Yellowknife, in the Northwest Territories, this 5 th day of December, 2016. FAIT à Yellowknife aux Territoires du Nord-Ouest, le 5 décembre 2016. Donna Allen Executive Director (Deputy Secretary-Treasurer) Law Society of the Northwest Territories Donna Allen Directrice exécutive (Secrétaire-trésorière adjointe) Barreau des Territoires du Nord-Ouest 211

PROPERTY ASSESSMENT AND TAXATION ACT NOTICE OF PUBLIC AUCTION OF PROPERTIES Pursuant to subection 97.7(2) of the Property Assessment and Taxation Act, R.S.N.W.T. 1988, c.p-10 and amendments thereto, the Municipal Corporation of the Town of Inuvik wishes to advise that the following properties may be offered for public auction if the arrears of property taxes and the current and subsequent expenses incurred by the Town to collect the arrears are not paid before January 18, 2017: LOT BLK /GRP PLAN PROPERTY ADDRESS MINIMUM SALE PRICE 10 28 228 6 Spruce Hill Drive $ 60,350.00 10 46 564 81 Wolverine Road $ 52,100.00 10 70 929 35 Ruyant Crescent $ 28,600,00 2 45 2098 24 Unit Row Housing $ 115,950.00 47 20 2319 175 Mackenzie Road $ 114,900.00 212

LOI SUR L ÉVALUATION ET L IMPÔT FONCIERS AVIS DE VENTE DE PROPRIÉTÉS AUX ENCHÈRES PUBLIQUES En application du paragraphe 97.7(2) de la Loi sur l évaluation et l impôt fonciers, L.R.T.N.-O. 1988, ch. P-10, avec ses modifications successives, la municipalité de la ville d Inuvik annonce que les propriétés suivantes peuvent être mises en vente aux enchères publiques si les arriérés d impôt foncier et les dépenses courantes et ultérieures engagées par la ville pour la perception de ces arriérés ne sont pas acquittés avant le 18 janvier 2017 : LOT BLOC / GROUPE PLAN ADRESSE DE LA PROPRIÉTÉ PRIX DE VENTE MINIMAL 10 28 228 6 Spruce Hill Drive 60 350,00 $ 10 46 564 81 Wolverine Road 52 100,00 $ 10 70 929 35 Ruyant Crescent 28 600,00 $ 2 45 2098 24 Unit Row Housing 115 950,00 $ 47 20 2319 175 Mackenzie Road 114 900,00 $ 213

Please be advised of the following: The public auction is set for January 18, 2017, at Council Chambers, Town Hall, Inuvik, NT at 9:00 a.m. If prior to commencement of the public auction, any person including the assessed owner pays the arrears of property taxes and all reasonable expenses incurred by the Town of Inuvik to collect the arrears with respect to a taxable property, the property will not be offered for auction. Each property shall be auctioned on the condition that taxes are two (2) years in arrears at the time of auction. The minimum sale price shall not be less that 50% of the assessed value as listed for each property. A property shall not be auctioned to the assessed owner of the property for less than the amount of tax arrears owing. Any person who pays the arrears of property taxes and expenses prior to commencement of the public auction may obtain a lien on the taxable property for the amount paid if that person is not the assessed owner and that person has an interest, estate, encumbrance or claim registered or filed under the Land Titles Act in or against the taxable property or is a transferee of such a person. The assessed owner of any of the above taxable properties is entitled to redeem that taxable property within 30 days after the date of the public auction by paying the Town of Inuvik the arrears of property taxes and all reasonable expenses incurred by the Town of Inuvik to collect the arrears. Where a taxable property that is sold at the public auction is redeemed by its assessed owner, the sale cannot be completed and all rights and interests of the purchaser in the taxable property cease. If a taxable property is sold at the public auction, every existing interest, estate, encumbrance or claim in or against the taxable property, will be extinguished, other than: a caveat registered under the Land Titles Act in respect of - a restrictive covenant; - an easement, including a utility easement; - an easement agreement, including a party wall agreement; a restrictive covenant or an easement, including a utility easement; an easement agreement, including a party wall agreement; a reservation or interest to which the property is subject under paragraphs 69(a), (c) and (d) of the Land Titles Act; an interest, estate, encumbrance or claim of Her Majesty in right of Canada; an interest, estate, encumbrance, or claim that is prescribed or of a prescribed class. Lawson Lundell LLP Barristers & Solicitors P.O. Box 818 200-4915 48 th Street YK Centre East YELLOWKNIFE, NT X1A 2N6 Attention: Alyssa Holland 214

Soyez avisés que : La vente aux enchères aura lieu à 9 h, le 18 janvier 2017, à la salle du conseil de l hôtel de ville d Inuvik, T.N.-O. La propriété ne sera pas mise en vente aux enchères si, avant le début des enchères publiques, quelqu un, y compris le propriétaire évalué, rembourse les arriérés d impôt foncier et toutes les dépenses raisonnables engagées par la ville d Inuvik pour la perception de ces arriérés. Chaque propriété est mise en vente aux enchères à condition que les arriérés d impôts fonciers soient accumulés sur une période de deux ans à la date des enchères. Le prix de vente minimal applicable à chaque propriété n est pas inférieur à 50 % de la valeur évaluée, tel qu énuméré. Une propriété n est pas vendue aux enchères au propriétaire évalué pour un montant inférieur au montant des impôts fonciers exigibles. À l exception du propriétaire évalué, la personne qui rembourse les arriérés d impôt foncier et les dépenses, avant le début des enchères publiques, et qui a un intérêt, un domaine, une charge ou une réclamation enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur les titres de biens-fonds à l égard de la propriété imposable, ou le cessionnaire de cette personne, peut avoir un privilège sur la propriété imposable pour le montant remboursé. Le propriétaire évalué d une propriété imposable vendue aux enchères publiques peut, dans les 30 jours suivant les enchères publiques, racheter la propriété imposable en remboursant à la ville d Inuvik les arriérés d impôt foncier et les dépenses raisonnables engagées par cette dernière pour la perception de ces arriérés. Lorsqu une propriété imposable vendue aux enchères publiques est ainsi rachetée par son propriétaire évalué, la vente aux enchères ne peut être conclue et les droits et intérêts de l acheteur dans la propriété sont éteints. La vente aux enchères publiques d une propriété imposable éteint tout intérêt, domaine, charge ou réclamation à l égard de cette propriété, sauf : une opposition enregistrée en vertu de la Loi sur les titres de biens-fonds relativement à : - une clause restrictive; - une servitude, y compris une servitude d utilité publique; - une entente visant une servitude, y compris une entente visant un mur mitoyen; une clause restrictive ou une servitude, y compris une servitude d utilité publique; une entente visant une servitude, y compris une entente visant un mur mitoyen; une clause de réserve ou un intérêt dont la propriété fait l objet aux termes des alinéas 69a), c) et d) de la Loi sur les titres de biens-fonds; tout intérêt, domaine, charge ou réclamation de Sa Majesté du chef du Canada; tout intérêt, domaine, charge ou réclamation prescrit ou d une catégorie prescrite. Lawson Lundell LLP Avocats et conseillers juridiques Case postale 818 200, 4915-48 e Rue YK Centre East YELLOWKNIFE T.N.-O. X1A 2N6 Attention: Alyssa Holland Territorial Printer, 2016 Yellowknife, N.W.T. L imprimeur territorial, 2016 Yellowknife (T. N.-O.) 215